-
A1 GRAB HIRE LIMITED - Suite 1b1 Argyle House, Northside, Joel Street, Northwood, Middlesex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08561429
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 1b1 Argyle House, Northside
- Joel Street
- Northwood
- Middlesex
- HA6 1NW
- United Kingdom Suite 1b1 Argyle House, Northside, Joel Street, Northwood, Middlesex, HA6 1NW, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CONSTABLE, Chad Antony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-07 10 Jahre
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Chad Antony Constable
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- A1 WASTE RECYCLING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-21
- Letzte Einreichung: 2023-06-07
-
A1 GRAB HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- A1 GRAB HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08561429. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.06.2013 registriert. A1 GRAB HIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen A1 WASTE RECYCLING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 1B1 Argyle House, Northside erreicht werden.
Jetzt sichern A1 GRAB HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A1 Grab Hire Limited - Suite 1b1 Argyle House, Northside, Joel Street, Northwood, Middlesex, Grossbritannien
- 2013-06-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A1 GRAB HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-06-28) - GAZ1
-
capital-name-of-class-of-shares (2022-03-03) - SH08
-
capital-allotment-shares (2022-02-28) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-01) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-07-16) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-15) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-07-13) - DISS16(SOAS)
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-22) - AAMD
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-22) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-06) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-07-27) - DISS16(SOAS)
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-10) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-11) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-31) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-14) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-04-15) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-07-15) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-01-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-18) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-27) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-04-21) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-27) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-14) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-30) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-10-13) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-10-06) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-11-12) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-11-12) - CONNOT
-
incorporation-company (2013-06-07) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-11-12) - AA01