-
QUEENSBURY PROPERTY ASSETS LIMITED - 9 Lisson Grove, Hale, Altrincham, WA15 9AE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08557593
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Lisson Grove
- Hale
- Altrincham
- WA15 9AE
- England 9 Lisson Grove, Hale, Altrincham, WA15 9AE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROOKE, Charles Edward
- GOLDING, David John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.06.2013
- Gelöscht am:
- 2023-07-25
- SIC/NACE
- 98000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David John Golding
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2021-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-01
- Letzte Einreichung: 2020-05-18
-
QUEENSBURY PROPERTY ASSETS LIMITED Firmenbeschreibung
- QUEENSBURY PROPERTY ASSETS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08557593. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "98000" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 9 Lisson Grove erreicht werden.
Jetzt sichern QUEENSBURY PROPERTY ASSETS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Queensbury Property Assets Limited - 9 Lisson Grove, Hale, Altrincham, WA15 9AE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUEENSBURY PROPERTY ASSETS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-05-09) - GAZ1
-
gazette-dissolved-compulsory (2023-07-25) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-23) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2022-05-10) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-11) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-05-12) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-29) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-31) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-28) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-24) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-22) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-03-09) - AA01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-08-11) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-31) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-11) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-29) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-02-12) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-24) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-10) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-19) - MR01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2014-02-10) - AP02
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-30) - AD01
-
incorporation-company (2013-06-05) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2013-10-03) - TM01