-
LIBERTY COACHES NE LTD - Liberty House, Station Road, Cramlington, NE23 8BH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08553448
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Liberty House
- Station Road
- Cramlington
- NE23 8BH
- England Liberty House, Station Road, Cramlington, NE23 8BH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HURST, Hugh Magill
- TURNER, Kenneth
- SKIERSKI, Pawel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-03 11 Jahre
- SIC/NACE
- 49319
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Hugh Magill Hurst
- -
- Mr Kenneth Turner
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- PHOENIX COACHES (NE) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-07-31
- Letzte Einreichung: 2023-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-21
- Letzte Einreichung: 2024-02-07
-
LIBERTY COACHES NE LTD Firmenbeschreibung
- LIBERTY COACHES NE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08553448. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.06.2013 registriert. LIBERTY COACHES NE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PHOENIX COACHES (NE) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49319" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Liberty House erreicht werden.
Jetzt sichern LIBERTY COACHES NE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Liberty Coaches Ne Ltd - Liberty House, Station Road, Cramlington, NE23 8BH, Grossbritannien
- 2013-06-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIBERTY COACHES NE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-updates (2024-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-14) - AA
-
capital-allotment-shares (2024-03-20) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-05-28) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-05-29) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2024-01-17) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-09-11) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-09-11) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-11-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-15) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-11-01) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-09-26) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-11-01) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-06-30) - PSC04
-
memorandum-articles (2022-02-11) - MA
-
resolution (2022-02-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2022-02-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-10-05) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-10-05) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-11) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-20) - CS01
-
resolution (2020-08-14) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-08-14) - MA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-13) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-11) - PSC07
-
memorandum-articles (2020-07-06) - MA
-
resolution (2020-07-06) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-02) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-09-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-08) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-06-05) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-03) - NEWINC