-
TOUCHSTONE BATHROOMS LIMITED - Lime Tree House 16 Pound Street, Wendover, Aylesbury, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08549845
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lime Tree House 16 Pound Street
- Wendover
- Aylesbury
- Buckinghamshire
- HP22 6EJ
- England Lime Tree House 16 Pound Street, Wendover, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 6EJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SIMMONS, Timothy John
- Prokuristen
- QUORUM SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.05.2013
- Alter der Firma 2013-05-30 11 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Timothy John Simmons
- Timothy John Simmons
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-13
- Letzte Einreichung: 2022-05-30
-
TOUCHSTONE BATHROOMS LIMITED Firmenbeschreibung
- TOUCHSTONE BATHROOMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08549845. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.05.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Lime Tree House 16 Pound Street erreicht werden.
Jetzt sichern TOUCHSTONE BATHROOMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Touchstone Bathrooms Limited - Lime Tree House 16 Pound Street, Wendover, Aylesbury, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2013-05-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOUCHSTONE BATHROOMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-08) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-15) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-06-08) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-06-08) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-06-08) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-12) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-05-04) - SH08
-
resolution (2021-05-04) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-05-04) - MA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2019-12-13) - CH04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-01-31) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-01-31) - AD02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-14) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-04) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-27) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-25) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-10-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-04) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-08-14) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-07) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-02-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-05-30) - NEWINC