-
REMIX BIDCO LIMITED - Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08542553
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kernick Industrial Estate
- Penryn
- Cornwall
- TR10 9LU Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARK, Robin John
- WILLIAMS, Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2013
- Gelöscht am:
- 2021-03-30
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Remix Topco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-06
- Letzte Einreichung: 2020-05-23
-
REMIX BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- REMIX BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08542553. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.05.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Kernick Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern REMIX BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Remix Bidco Limited - Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REMIX BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-02-06) - SOAS(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-01-04) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-01-12) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-07-08) - CAP-SS
-
resolution (2020-07-08) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-02) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-14) - CH01
-
legacy (2020-07-08) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-07-08) - SH19
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-31) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-08) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-24) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-10-25) - MR04
-
resolution (2014-08-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-22) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-13) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-08) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-08-08) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-11) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-06-07) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-06-07) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-25) - AD01
-
incorporation-company (2013-05-23) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2013-06-07) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-26) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-27) - AP01
-
resolution (2013-07-08) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-07-08) - SH02
-
capital-allotment-shares (2013-06-27) - SH01