-
VOCA TELEMARKETING LIMITED - 92 London Street, Reading, Berkshire, RG1 4SJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08509053
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 92 London Street
- Reading
- Berkshire
- RG1 4SJ 92 London Street, Reading, Berkshire, RG1 4SJ UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.04.2013
- Gelöscht am:
- 2020-09-30
- SIC/NACE
- 82200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Victoria Joanne Edwards
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-01-31
- Letzte Einreichung: 2016-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-05-13
- Letzte Einreichung: 2017-04-29
-
VOCA TELEMARKETING LIMITED Firmenbeschreibung
- VOCA TELEMARKETING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08509053. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.04.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82200" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 92 London Street erreicht werden.
Jetzt sichern VOCA TELEMARKETING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Voca Telemarketing Limited - 92 London Street, Reading, Berkshire, RG1 4SJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VOCA TELEMARKETING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-09-30) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-06-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-25) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-01-21) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-01-21) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-05-26) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-23) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-05-15) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-05-15) - 600
-
resolution (2018-05-15) - RESOLUTIONS
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-04-26) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-04-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-14) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-10) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-08) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-03-02) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-06) - AD01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-10-19) - SH02
-
capital-allotment-shares (2015-10-08) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-13) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-06-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-04-29) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2013-09-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-10) - TM01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2013-05-07) - AP02