-
JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD - Highdale House 7 Centre Court, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08500923
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Highdale House 7 Centre Court
- Treforest Industrial Estate
- Pontypridd
- Rhondda Cynon Taff
- CF37 5YR
- Wales Highdale House 7 Centre Court, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, CF37 5YR, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- BELL, Sara Louise
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2013
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 35140
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Tempus Energy Technology Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- TEMPUS ENERGY SUPPLY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-12
- Letzte Einreichung: 2019-11-28
-
JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD Firmenbeschreibung
- JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08500923. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.04.2013 registriert. JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TEMPUS ENERGY SUPPLY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35140" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Highdale House 7 Centre Court erreicht werden.
Jetzt sichern JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jetstream Energy Supply Ltd - Highdale House 7 Centre Court, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JETSTREAM ENERGY SUPPLY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-24) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-16) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-20) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-16) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-21) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-15) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-16) - TM01
-
resolution (2016-08-18) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company (2016-10-25) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-23) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-01) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-07) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-05-02) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-02) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-07-02) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2014-07-02) - TM01
-
resolution (2014-07-10) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-07-10) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-15) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-11-25) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-28) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-28) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-12) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-08-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-11-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-02) - AP01
-
incorporation-company (2013-04-23) - NEWINC