-
TEVTEC LIMITED - Pexion Limited, George Street, Chorley, PR7 2BE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08481748
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pexion Limited
- George Street
- Chorley
- PR7 2BE
- England Pexion Limited, George Street, Chorley, PR7 2BE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRINDLE, David James
- TURNER, Darren James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.04.2013
- Alter der Firma 2013-04-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Pexion Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-23
- Letzte Einreichung: 2021-04-09
-
TEVTEC LIMITED Firmenbeschreibung
- TEVTEC LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08481748. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.04.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Pexion Limited erreicht werden.
Jetzt sichern TEVTEC LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tevtec Limited - Pexion Limited, George Street, Chorley, PR7 2BE, Grossbritannien
- 2013-04-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TEVTEC LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-22) - CS01
-
legacy (2021-10-13) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-10-13) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-10-13) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-10-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-03-29) - AA
-
legacy (2021-03-26) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-03-26) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-03-26) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-12-15) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
legacy (2019-07-16) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-07-16) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-07-16) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
legacy (2018-07-19) - GUARANTEE2
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-01-03) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-03) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-03) - PSC02
-
resolution (2018-01-23) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-10) - CS01
-
legacy (2018-07-19) - AGREEMENT2
-
legacy (2018-07-19) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-07-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-01-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-12) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-01-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-05-27) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-01-29) - AP03
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-05-02) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-02) - MR01
-
incorporation-company (2013-04-09) - NEWINC