-
PARKWAY INVESTMENTS LIMITED - Parkway House Second Avenue, Centrum One Hundred, Burton-On-Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08468914
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Parkway House Second Avenue
- Centrum One Hundred
- Burton-On-Trent
- Staffordshire
- DE14 2WF Parkway House Second Avenue, Centrum One Hundred, Burton-On-Trent, Staffordshire, DE14 2WF UK
Management
- Geschäftsführung
- MUGGLESTONE, Dean Graham
- ROWE, Andrew John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.04.2013
- Alter der Firma 2013-04-02 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew John Rowe
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-01-14
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
-
PARKWAY INVESTMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- PARKWAY INVESTMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08468914. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.04.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Parkway House Second Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern PARKWAY INVESTMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Parkway Investments Limited - Parkway House Second Avenue, Centrum One Hundred, Burton-On-Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2013-04-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PARKWAY INVESTMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-09) - AA
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-04-13) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-04-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-01-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-10) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-23) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-04-07) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-27) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-15) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-30) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-03-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-23) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-23) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-15) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-08-21) - AA01
-
incorporation-company (2013-04-02) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-10-15) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-15) - AP01