-
BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED - Cadbury House Frost Hill, Congresbury, Bristol, BS49 5AD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08465874
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cadbury House Frost Hill
- Congresbury
- Bristol
- BS49 5AD Cadbury House Frost Hill, Congresbury, Bristol, BS49 5AD UK
Management
- Geschäftsführung
- BOSS, Jonathan Robin
- TAPLIN, Nicholas James
- WHITE, Marco Pierre
- WILCE, Caroline Jayne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-28 11 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Black And White Hospitality Management Ltd
- Corsham Estate Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- NEW YORK ITALIAN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-11
- Letzte Einreichung: 2023-03-28
-
BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED Firmenbeschreibung
- BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08465874. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.03.2013 registriert. BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEW YORK ITALIAN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cadbury House Frost Hill erreicht werden.
Jetzt sichern BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Black And White Hospitality Limited - Cadbury House Frost Hill, Congresbury, Bristol, BS49 5AD, Grossbritannien
- 2013-03-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLACK AND WHITE HOSPITALITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-03-29) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-09-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-05) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-08) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-06) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-02-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
-
resolution (2016-03-14) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-04-12) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-24) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-16) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-17) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-27) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-05-17) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-05-17) - SH01
-
incorporation-company (2013-03-28) - NEWINC
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-05-17) - SH02