-
SIKA TEXTILES LIMITED - 59 Abbeygate Street, Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1LB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08459466
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 59 Abbeygate Street
- Bury St Edmunds
- Suffolk
- IP33 1LB 59 Abbeygate Street, Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1LB UK
Management
- Geschäftsführung
- REID, Christina Ann
- REID, Keith
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Christina Ann Reid
- Mr Keith Reid
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-08
- Letzte Einreichung: 2023-03-25
-
SIKA TEXTILES LIMITED Firmenbeschreibung
- SIKA TEXTILES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08459466. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 59 Abbeygate Street erreicht werden.
Jetzt sichern SIKA TEXTILES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sika Textiles Limited - 59 Abbeygate Street, Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1LB, Grossbritannien
- 2013-03-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIKA TEXTILES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-06-03) - DS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-27) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-04-03) - PSC09
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2019-04-03) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-08) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-12) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
memorandum-articles (2018-07-31) - MA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
-
resolution (2018-07-31) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-08-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-03-26) - SH01
-
incorporation-company (2013-03-25) - NEWINC