-
KCC 1 LTD - 14 Bedford Square, London, WC1B 3JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08438917
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 Bedford Square
- London
- WC1B 3JA 14 Bedford Square, London, WC1B 3JA UK
Management
- Geschäftsführung
- MERCHANT, Mohammad Reza Aslam
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-11 11 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Kcc 1 Midco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800C3BCY87NLICD63
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-25
- Letzte Einreichung: 2022-03-11
-
KCC 1 LTD Firmenbeschreibung
- KCC 1 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08438917. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 14 Bedford Square erreicht werden.
Jetzt sichern KCC 1 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kcc 1 Ltd - 14 Bedford Square, London, WC1B 3JA, Grossbritannien
- 2013-03-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KCC 1 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-01-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-11-28) - GAZ1
-
liquidation-receiver-cease-to-act-receiver (2023-07-22) - RM02
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-07-22) - REC2
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-07-05) - REC2
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-04-26) - AA
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2022-06-06) - RM01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-03-04) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-14) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-17) - CS01
-
resolution (2020-08-20) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-06) - AA
-
memorandum-articles (2020-08-20) - MA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-08-28) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-09-01) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-12-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-30) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-13) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-20) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-20) - PSC02
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-17) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-21) - DISS40
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-07-21) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-28) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-24) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-18) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-22) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-22) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-05) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-05) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-01) - AP01
-
legacy (2013-03-26) - MG01
-
incorporation-company (2013-03-11) - NEWINC