-
NICKEL PROJECTS LIMITED - Wolverton, 50 Hadley Road, Enfield, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08435364
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wolverton
- 50 Hadley Road
- Enfield
- London
- EN2 8JY Wolverton, 50 Hadley Road, Enfield, London, EN2 8JY UK
Management
- Geschäftsführung
- BEECH, Robert Adam
- GANNEY, Ian Keith
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.03.2013
- Gelöscht am:
- 2022-09-13
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian Ganney
- Mr Ian Ganney
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-02
- Letzte Einreichung: 2022-03-19
-
NICKEL PROJECTS LIMITED Firmenbeschreibung
- NICKEL PROJECTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08435364. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Wolverton erreicht werden.
Jetzt sichern NICKEL PROJECTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nickel Projects Limited - Wolverton, 50 Hadley Road, Enfield, London, Grossbritannien
- 2013-03-07
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NICKEL PROJECTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2023-06-16) - COCOMP
-
gazette-notice-compulsory (2023-06-06) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-13) - CS01
-
administrative-restoration-company (2023-01-13) - RT01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-06-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-dissolved-compulsory (2022-09-13) - GAZ2
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-04-12) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2022-03-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-17) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-16) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-16) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-29) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-27) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-27) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-10-28) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-08-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-02) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-29) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-06) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-07) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-20) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-10) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-18) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
second-filing-of-form-with-form-type (2013-04-26) - RP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-24) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-10) - TM01
-
incorporation-company (2013-03-07) - NEWINC