-
HORIZON STOCKBROKING LIMITED - 29 New Walk, Leicester, LE1 6TE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08434634
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 29 New Walk
- Leicester
- LE1 6TE 29 New Walk, Leicester, LE1 6TE UK
Management
- Geschäftsführung
- SWEENEY, Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 66220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Carr
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300GB6MZQQEJ5SE61
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-03-21
- Letzte Einreichung: 2017-03-07
-
HORIZON STOCKBROKING LIMITED Firmenbeschreibung
- HORIZON STOCKBROKING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08434634. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 29 New Walk erreicht werden.
Jetzt sichern HORIZON STOCKBROKING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Horizon Stockbroking Limited - 29 New Walk, Leicester, LE1 6TE, Grossbritannien
- 2013-03-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HORIZON STOCKBROKING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-01-30) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-01-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-12-07) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-31) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-08-13) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-07-25) - LIQ02
-
resolution (2018-07-25) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-06-12) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-13) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-26) - AP01
-
resolution (2017-07-03) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-05-30) - GAZ1
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-28) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-02) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-12-15) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-29) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-04-26) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-26) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-03-30) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-07-04) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-20) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-03-07) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-05) - AD01