-
A1 TRAFFIC SAFETY SERVICES LIMITED - Alexandra Dock Business Centre, Fishermans Wharf, Grimsby, DN31 1UL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08433591
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Alexandra Dock Business Centre
- Fishermans Wharf
- Grimsby
- DN31 1UL Alexandra Dock Business Centre, Fishermans Wharf, Grimsby, DN31 1UL UK
Management
- Geschäftsführung
- MCKAY, Patrick John
- MUSKER, Steven James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 52219
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Patrick John Mckay
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-29
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-21
- Letzte Einreichung: 2020-03-07
-
A1 TRAFFIC SAFETY SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- A1 TRAFFIC SAFETY SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08433591. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52219" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Alexandra Dock Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern A1 TRAFFIC SAFETY SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A1 Traffic Safety Services Limited - Alexandra Dock Business Centre, Fishermans Wharf, Grimsby, DN31 1UL, Grossbritannien
- 2013-03-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A1 TRAFFIC SAFETY SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-22) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-05) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-12) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-12) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-07) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-07) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-11) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-07) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-13) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-21) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-27) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-03-12) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-24) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-18) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-08-18) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-15) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-18) - TM01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-08-18) - CH03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-08-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-02) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-08) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-04-08) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2013-04-08) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-08) - AP01
-
incorporation-company (2013-03-07) - NEWINC