-
JOSHUA THOMAS CONSTRUCTION LIMITED - Wilson Field Limited The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08431365
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wilson Field Limited The Manor House
- 260 Ecclesall Road South
- Sheffield
- S11 9PS Wilson Field Limited The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.03.2013
- Gelöscht am:
- 2023-03-02
- SIC/NACE
- 42990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-02-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-10
- Letzte Einreichung:
-
JOSHUA THOMAS CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- JOSHUA THOMAS CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08431365. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.02.2015.Die Firma kann schriftlich über Wilson Field Limited The Manor House erreicht werden.
Jetzt sichern JOSHUA THOMAS CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Joshua Thomas Construction Limited - Wilson Field Limited The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JOSHUA THOMAS CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-08) - AD01
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2021-01-07) - LIQ06
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-01-08) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-07) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-08) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-01-02) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-06-17) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2017-02-28) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2016-12-05) - 2.34B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2016-07-18) - 2.24B
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-16) - TM01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2016-01-19) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-01-05) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-proposals (2016-01-05) - 2.17B
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-29) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-04) - AR01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2015-12-23) - 2.12B
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-22) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-04-01) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-20) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-06-25) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-08) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-26) - CH01
-
incorporation-company (2013-03-06) - NEWINC