-
LUMATA HOLDINGS LIMITED - 25, Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08425332
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25
- Moorgate
- London
- EC2R 6AY 25, Moorgate, London, EC2R 6AY UK
Management
- Geschäftsführung
- SPETZLER, Matthew Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.03.2013
- Gelöscht am:
- 2023-02-01
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Lumata Topco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- LUMATA NEWCO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-03-15
- Letzte Einreichung: 2017-03-01
-
LUMATA HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- LUMATA HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08425332. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.03.2013 registriert. LUMATA HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LUMATA NEWCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 erreicht werden.
Jetzt sichern LUMATA HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lumata Holdings Limited - 25, Moorgate, London, EC2R 6AY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LUMATA HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2020-05-15) - LIQ06
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-16) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-20) - 600
-
liquidation-resolution-miscellaneous (2020-05-20) - LIQ MISC RES
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-11-06) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-11-06) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-17) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-02-22) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-02-22) - 600
-
resolution (2018-02-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-02-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-15) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-16) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-11) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-20) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-08-01) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-07) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-10-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-20) - TM01
-
second-filing-of-form-with-form-type (2015-07-13) - RP04
-
capital-allotment-shares (2015-07-02) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-02) - TM01
-
resolution (2015-04-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-17) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-10-07) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-11-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-27) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-04-23) - RESOLUTIONS
-
resolution (2013-04-05) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-03-01) - AA01
-
capital-allotment-shares (2013-04-10) - SH01
-
memorandum-articles (2013-04-23) - MEM/ARTS
-
incorporation-company (2013-03-01) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2013-07-01) - SH01
-
resolution (2013-07-22) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-03) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-04) - AP01
-
change-of-name-notice (2013-04-05) - CONNOT
-
termination-director-company-with-name (2013-10-24) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-16) - CERTNM