-
COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED - Alexander House, Waters Edge Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08419584
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Alexander House
- Waters Edge Business Park
- Stoke-On-Trent
- Staffordshire
- ST4 4DB Alexander House, Waters Edge Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST4 4DB UK
Management
- Geschäftsführung
- CHANTLER, Simon
- LAMONT, Neil John Duncan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.02.2013
- Gelöscht am:
- 2020-02-20
- SIC/NACE
- 41100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2016-02-29
-
COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED Firmenbeschreibung
- COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08419584. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.02.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29.02.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Alexander House erreicht werden.
Jetzt sichern COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Combined Development Partnerships (Winsford) Limited - Alexander House, Waters Edge Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-20) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-11) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2019-11-20) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-20) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-27) - LIQ03
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-03-31) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-13) - AD01
-
resolution (2017-03-09) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2017-03-09) - 4.70
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-02) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-28) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-31) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-05-24) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-05-24) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-22) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-05-17) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-12) - TM01
-
incorporation-company (2013-02-26) - NEWINC