-
CARELINE GROUP LIMITED - 25 Meer Street, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 6QB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08418618
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Meer Street
- Stratford-Upon-Avon
- Warwickshire
- CV37 6QB
- England 25 Meer Street, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 6QB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Box Clever Software Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- POMBERO PRODUCTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-11
- Letzte Einreichung: 2024-02-25
-
CARELINE GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- CARELINE GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08418618. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.02.2013 registriert. CARELINE GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen POMBERO PRODUCTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 Meer Street erreicht werden.
Jetzt sichern CARELINE GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Careline Group Limited - 25 Meer Street, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 6QB, Grossbritannien
- 2013-02-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CARELINE GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-updates (2024-02-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-11) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-07-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-19) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-12-16) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-13) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-11-29) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-20) - TM01
-
resolution (2016-05-16) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-03-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-12) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-03-22) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-03-28) - SH02
-
termination-director-company-with-name (2013-12-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-05) - AP01
-
incorporation-company (2013-02-25) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-11) - AP01