-
WATERFIELDS HOTEL LTD - 21 Rockcliffe Grange, Mansfield, NG18 4YW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08399923
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21 Rockcliffe Grange
- Mansfield
- NG18 4YW
- England 21 Rockcliffe Grange, Mansfield, NG18 4YW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GRIFFIN, Nigel Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-12 11 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Karman Ltd.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ALEXANDER JAMES PRIVATE EQUITY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-20
- Letzte Einreichung: 2021-03-06
-
WATERFIELDS HOTEL LTD Firmenbeschreibung
- WATERFIELDS HOTEL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08399923. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2013 registriert. WATERFIELDS HOTEL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALEXANDER JAMES PRIVATE EQUITY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 21 Rockcliffe Grange erreicht werden.
Jetzt sichern WATERFIELDS HOTEL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Waterfields Hotel Ltd - 21 Rockcliffe Grange, Mansfield, NG18 4YW, England, Grossbritannien
- 2013-02-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WATERFIELDS HOTEL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-09) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-07) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-01-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-28) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-28) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-06-21) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-28) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-08) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-07) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2018-07-18) - MR05
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-07-10) - AP02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-19) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-19) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-23) - MR01
-
capital-allotment-shares (2018-11-02) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-01) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-08) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-22) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-11-26) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-06) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-01) - PSC05
-
capital-allotment-shares (2018-02-28) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-28) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
-
change-of-name-notice (2017-04-12) - CONNOT
-
resolution (2017-04-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-06-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-08-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-04-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-02-12) - NEWINC