-
WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD - 8 Bloomsbury Street, London, WC1B 3SR, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08397697
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Bloomsbury Street
- London
- WC1B 3SR
- England 8 Bloomsbury Street, London, WC1B 3SR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BONAVERO, Olivier Maurice Henri
- COXHEAD, Mark Leonard
- EDDOWES, Robert James
- SPITERI, Mark Richard Anthony
- MILES, Sebastian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-11 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Markus Stutz
- -
- Mr Olivier Maurice Henri Bonavero
- -
- Mr Mark Leonard Coxhead
- Mr Mark Richard Anthony Spiteri
- Mr Robert James Eddowes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- WOODSFORD SCF LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300JHEF60GGV0P298
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-29
- Letzte Einreichung: 2023-06-15
-
WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD Firmenbeschreibung
- WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08397697. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.02.2013 registriert. WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WOODSFORD SCF LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 Bloomsbury Street erreicht werden.
Jetzt sichern WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Woodsford Tradebridge Ltd - 8 Bloomsbury Street, London, WC1B 3SR, England, Grossbritannien
- 2013-02-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WOODSFORD TRADEBRIDGE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-15) - CS01
-
capital-allotment-shares (2023-02-28) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-03-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-08-04) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-02-14) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-08-04) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-08-04) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-27) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-20) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-10-19) - SH01
-
capital-allotment-shares (2021-01-20) - SH01
-
capital-allotment-shares (2021-05-19) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-31) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-31) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-11) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-12-20) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-09-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-02) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-08-08) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-11) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-11-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-11-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-21) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-04-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-02-11) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2013-08-20) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-07) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-17) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-10-03) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-20) - AR01