-
NEWSTAY MANCHESTER LIMITED - 7 Albemarle Street, London, W1S 4HQ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08391486
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7 Albemarle Street
- London
- W1S 4HQ
- England 7 Albemarle Street, London, W1S 4HQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KRAIS, Ashley Simon
- MOHAMED, Maqboolali
- Prokuristen
- CITCO MANAGEMENT (UK) LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-06 11 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Wne Victoria Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-01
- Letzte Einreichung: 2023-12-18
-
NEWSTAY MANCHESTER LIMITED Firmenbeschreibung
- NEWSTAY MANCHESTER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08391486. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.02.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 7 Albemarle Street erreicht werden.
Jetzt sichern NEWSTAY MANCHESTER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Newstay Manchester Limited - 7 Albemarle Street, London, W1S 4HQ, England, Grossbritannien
- 2013-02-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEWSTAY MANCHESTER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-03-03) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-12-01) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-11-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-11-02) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-03) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-02-14) - TM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-12-20) - PSC05
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2023-02-14) - AP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-14) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-02-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-22) - CS01
-
capital-allotment-shares (2022-11-11) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-02-16) - PSC05
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-21) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-27) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-18) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-02-18) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-07-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-06-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-05) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-21) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-10) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-08-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-05-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-07-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-11) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-01-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
memorandum-articles (2013-04-03) - MEM/ARTS
-
resolution (2013-04-03) - RESOLUTIONS
-
legacy (2013-04-02) - MG01
-
incorporation-company (2013-02-06) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-21) - AA01