-
BRADBURY'S OF BRISTOL LIMITED - QUALITY KITCHENS HOLDINGS LTD, Suite 133 2-4 Heath Place, Bognor Regis, West Sussex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08374499
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- QUALITY KITCHENS HOLDINGS LTD
- Suite 133 2-4 Heath Place
- Bognor Regis
- West Sussex
- PO22 9SL
- England QUALITY KITCHENS HOLDINGS LTD, Suite 133 2-4 Heath Place, Bognor Regis, West Sussex, PO22 9SL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BREW, Robert Terence
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.01.2013
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 47599
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bradbury's (Holdings) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-07
- Letzte Einreichung: 2020-01-24
-
BRADBURY'S OF BRISTOL LIMITED Firmenbeschreibung
- BRADBURY'S OF BRISTOL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08374499. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 24.01.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47599" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Quality Kitchens Holdings Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern BRADBURY'S OF BRISTOL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bradbury's Of Bristol Limited - QUALITY KITCHENS HOLDINGS LTD, Suite 133 2-4 Heath Place, Bognor Regis, West Sussex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRADBURY'S OF BRISTOL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-17) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-06) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-17) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-07) - CS01
-
change-person-director-company (2019-10-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-05-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-21) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-18) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-14) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-05) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-29) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-26) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-31) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-06) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-11-06) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-11-06) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-11) - AP01
-
auditors-resignation-company (2014-11-14) - AUD
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-11-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
legacy (2013-02-26) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-02-22) - AA01
-
incorporation-company (2013-01-24) - NEWINC