-
WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED - 59 Oakdale Drive Oakdale Drive, Shipley, West Yorkshire, BD18 1PD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08373077
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 59 Oakdale Drive Oakdale Drive
- Shipley
- West Yorkshire
- BD18 1PD
- England 59 Oakdale Drive Oakdale Drive, Shipley, West Yorkshire, BD18 1PD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- RAYNER, Michael John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-24 11 Jahre
- SIC/NACE
- 45190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Michael John Rayner
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- TRUHAR CRAFTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-22
- Letzte Einreichung: 2024-03-08
-
WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED Firmenbeschreibung
- WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08373077. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.01.2013 registriert. WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TRUHAR CRAFTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45190" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 59 Oakdale Drive Oakdale Drive erreicht werden.
Jetzt sichern WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: West Yorkshire Truck & Van Sales Limited - 59 Oakdale Drive Oakdale Drive, Shipley, West Yorkshire, BD18 1PD, Grossbritannien
- 2013-01-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WEST YORKSHIRE TRUCK & VAN SALES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-25) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2024-05-28) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-05-29) - DISS40
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-11-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-08) - CS01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2023-03-08) - RP04AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-07) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-07) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-03-07) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-26) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-26) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-26) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-02-26) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-11-10) - AP03
-
resolution (2020-06-11) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-30) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-07) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-07) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-07) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-08-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-25) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-18) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2013-01-24) - TM01
-
incorporation-company (2013-01-24) - NEWINC