-
PURE INSIGHT LTD - Rmt, Gosforth Park Avenue, Newcastle, NE12 8EG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08371587
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Rmt
- Gosforth Park Avenue
- Newcastle
- NE12 8EG Rmt, Gosforth Park Avenue, Newcastle, NE12 8EG UK
Management
- Geschäftsführung
- WARREN, Anna Charles
- WARREN, Sean Michael
- Prokuristen
- WARREN, Sean Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.01.2013
- Gelöscht am:
- 2021-01-30
- SIC/NACE
- 70229
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- IMBROGLIOUK LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-03-31
- Letzte Einreichung: 2015-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2016-01-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-02-06
- Letzte Einreichung:
-
PURE INSIGHT LTD Firmenbeschreibung
- PURE INSIGHT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08371587. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.01.2013 registriert. PURE INSIGHT LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen IMBROGLIOUK LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.01.2016.Die Firma kann schriftlich über Rmt erreicht werden.
Jetzt sichern PURE INSIGHT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pure Insight Ltd - Rmt, Gosforth Park Avenue, Newcastle, NE12 8EG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PURE INSIGHT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-10-30) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-08-03) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-08-03) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-30) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2017-03-23) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2017-03-23) - 4.40
-
liquidation-disclaimer-notice (2017-02-17) - F10.2
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-11-17) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-11-17) - 600
-
resolution (2016-11-17) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-19) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-06-25) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-05) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-02-05) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-11-25) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-25) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-part (2013-11-18) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-23) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-16) - MR01
-
capital-allotment-shares (2013-07-09) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-28) - CERTNM
-
resolution (2013-06-21) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2013-01-23) - NEWINC