-
GREYFORT SERVICES LIMITED - Impney Hall, Impney Estate, Droitwich Spa, WR9 0BN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08370089
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Impney Hall
- Impney Estate
- Droitwich Spa
- WR9 0BN
- England Impney Hall, Impney Estate, Droitwich Spa, WR9 0BN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SPOLLON, Guy
- SPOLLON, Roderick William Merton
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-22 11 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Greyfort Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PAULJAY INVESTMENT COMPANY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-05
- Letzte Einreichung: 2021-01-22
-
GREYFORT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- GREYFORT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08370089. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.01.2013 registriert. GREYFORT SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PAULJAY INVESTMENT COMPANY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Impney Hall erreicht werden.
Jetzt sichern GREYFORT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greyfort Services Limited - Impney Hall, Impney Estate, Droitwich Spa, WR9 0BN, Grossbritannien
- 2013-01-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREYFORT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-10-30) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-10-30) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-01-06) - AA
-
legacy (2020-01-06) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-01-06) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-01-06) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-10-30) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-01-09) - AA
-
legacy (2019-01-09) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-01-09) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-01-09) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-11-28) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-11-28) - AA
-
legacy (2017-11-28) - AGREEMENT2
-
legacy (2017-11-28) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
legacy (2016-02-11) - SH20
-
resolution (2016-02-17) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-04-11) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-02-11) - SH19
-
legacy (2016-02-11) - CAP-SS
-
resolution (2016-02-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-02-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-28) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2016-01-28) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-18) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-04) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-10-17) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-08-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-04) - AD01
-
resolution (2013-05-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-18) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-03-05) - AA01
-
resolution (2013-02-05) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-28) - AP01
-
incorporation-company (2013-01-22) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2013-08-05) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-01) - MR01