-
ABSOLUTE RENEWABLE ENERGY (UK) LIMITED - 340, Deansgate, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08368431
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 340
- Deansgate
- Manchester
- Manchester
- M3 4LY 340, Deansgate, Manchester, Manchester, M3 4LY UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDERSON, Gordon Graham
- BURKE, Anthony
- KERSHAW, Keith
- MORLEY, Andrew
- TAPPIN, Nicholas Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.01.2013
- Gelöscht am:
- 2023-07-24
- SIC/NACE
- 43999
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-02-04
- Letzte Einreichung:
-
ABSOLUTE RENEWABLE ENERGY (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- ABSOLUTE RENEWABLE ENERGY (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08368431. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.01.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 340 erreicht werden.
Jetzt sichern ABSOLUTE RENEWABLE ENERGY (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Absolute Renewable Energy (Uk) Limited - 340, Deansgate, Manchester, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ABSOLUTE RENEWABLE ENERGY (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-06-30) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-03-17) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-03-01) - 600
-
resolution (2016-03-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2016-02-17) - MR05
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-01-05) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2015-01-05) - MA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-01-05) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-05) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-05) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-18) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-21) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-17) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-16) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-05-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-29) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-04-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-secretary-company-with-name (2013-01-21) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-21) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-21) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-12) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-06-24) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-06-24) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-11) - AP01
-
incorporation-company (2013-01-21) - NEWINC