-
D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD - C/O Leonard Curtis 6th Floor, Walker House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08363121
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Leonard Curtis 6th Floor, Walker House
- Exchange Flags
- Liverpool
- Merseyside
- L2 3YL C/O Leonard Curtis 6th Floor, Walker House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL UK
Management
- Geschäftsführung
- MILLINGTON, Ian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-16 11 Jahre
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Ian Millington
- Mr Paul Christopher Baker
- Mr Ian Millington
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- DRIVER FROM P&S LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-27
- Letzte Einreichung: 2020-01-16
-
D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08363121. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.01.2013 registriert. D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DRIVER FROM P&S LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Leonard Curtis 6Th Floor, Walker House erreicht werden.
Jetzt sichern D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: D P Logistics Solutions Ltd - C/O Leonard Curtis 6th Floor, Walker House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
- 2013-01-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu D P LOGISTICS SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2022-01-14) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-07-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-28) - 600
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-14) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-04-14) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-13) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-13) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-13) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-13) - AP01
-
resolution (2020-06-05) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-06-16) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-14) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-28) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-13) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-04-28) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-22) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-01-16) - NEWINC