-
DRENL LIMITED - Church Farm House Rectory Lane, Angmering, Littlehampton, BN16 4JU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08332548
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Church Farm House Rectory Lane
- Angmering
- Littlehampton
- BN16 4JU
- England Church Farm House Rectory Lane, Angmering, Littlehampton, BN16 4JU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRATHWAITE, James Everett
- CUTTILL, Paul Andrew
- ELLICK, Philip Frederick
- KELLY, Dominic Noel David Miles Charles
- MATTU, Tajinder Singh
- RILEY, Keith
- BRATHWAITE, Charlotte Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.12.2012
- Alter der Firma 2012-12-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Tajinder Singh Mattu
- -
- Mr Tajinder Singh Mattu
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-18
- Letzte Einreichung: 2021-07-04
-
DRENL LIMITED Firmenbeschreibung
- DRENL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08332548. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.12.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Church Farm House Rectory Lane erreicht werden.
Jetzt sichern DRENL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Drenl Limited - Church Farm House Rectory Lane, Angmering, Littlehampton, BN16 4JU, Grossbritannien
- 2012-12-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DRENL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-08) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-07) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-29) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-02-12) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-18) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-01-20) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-16) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-16) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-25) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-04-22) - SH02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-03-23) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-02-04) - SH01
-
resolution (2013-06-11) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-31) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-06-11) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-15) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-09-13) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-08) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-08-05) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-05-03) - SH02
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-12-17) - NEWINC