-
WHEALE PLANT HIRE LIMITED - 11 Warwick Road Old Trafford, Manchester, Greater Manchester, M16 0QQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08330421
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Warwick Road Old Trafford
- Manchester
- Greater Manchester
- M16 0QQ 11 Warwick Road Old Trafford, Manchester, Greater Manchester, M16 0QQ UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.12.2012
- Gelöscht am:
- 2021-12-07
- SIC/NACE
- 39000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr William Wheale
- Mr William Wheale
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- KT RECYCLING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-29
- Letzte Einreichung: 2020-10-15
-
WHEALE PLANT HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- WHEALE PLANT HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08330421. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.12.2012 registriert. WHEALE PLANT HIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KT RECYCLING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "39000" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 11 Warwick Road Old Trafford erreicht werden.
Jetzt sichern WHEALE PLANT HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wheale Plant Hire Limited - 11 Warwick Road Old Trafford, Manchester, Greater Manchester, M16 0QQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHEALE PLANT HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-05-21) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-04-13) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-26) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-23) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-29) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-29) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-31) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-07-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-16) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-23) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-05-23) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-11) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-11) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-08-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-12-13) - TM01
-
incorporation-company (2012-12-13) - NEWINC