-
SOUTH OF ENGLAND NATURAL BURIALS LIMITED - 1000 Lakeside, Western Road North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08322729
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1000 Lakeside
- Western Road North Harbour
- Portsmouth
- Hampshire
- PO6 3FE 1000 Lakeside, Western Road North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3FE UK
Management
- Geschäftsführung
- LEWIS, Gareth
- RALF, Mark Alexander
- SMITH, Mark Stephen
- VINCENT-PRIOR, Amber
- WILKINS, Gregory
- Prokuristen
- DOMINY, Silena Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2012
- Alter der Firma 2012-12-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 96030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- South Of England Funeral Partners Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-21
- Letzte Einreichung: 2020-12-07
-
SOUTH OF ENGLAND NATURAL BURIALS LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTH OF ENGLAND NATURAL BURIALS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08322729. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96030" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1000 Lakeside erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH OF ENGLAND NATURAL BURIALS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South Of England Natural Burials Limited - 1000 Lakeside, Western Road North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
- 2012-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH OF ENGLAND NATURAL BURIALS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-27) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-07-05) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-05-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-16) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-07-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-07-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-05-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-05-13) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-13) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-10) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-05-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-12-07) - NEWINC