-
ALL CERAMIC ESSENTIALS LTD - 2 Priestthorpe Lane, Bingley, Bradford, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08295809
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Priestthorpe Lane
- Bingley
- Bradford
- West Yorkshire
- BD16 4ED 2 Priestthorpe Lane, Bingley, Bradford, West Yorkshire, BD16 4ED UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Philip Michael
- Prokuristen
- SMITH, Sandra Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-15 11 Jahre
- SIC/NACE
- 47990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Philip Michael Smith
- Dr Andrew Richard Greenwood
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-29
- Letzte Einreichung: 2023-11-15
-
ALL CERAMIC ESSENTIALS LTD Firmenbeschreibung
- ALL CERAMIC ESSENTIALS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08295809. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 2 Priestthorpe Lane erreicht werden.
Jetzt sichern ALL CERAMIC ESSENTIALS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: All Ceramic Essentials Ltd - 2 Priestthorpe Lane, Bingley, Bradford, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2012-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALL CERAMIC ESSENTIALS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-voluntary (2024-01-16) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-01-08) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-12-14) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-20) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-27) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-29) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-06) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-26) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-19) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-27) - AR01
-
accounts-with-made-up-date (2014-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2013-12-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-12-23) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-16) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2013-12-16) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-08-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-05-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-05-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-11-15) - NEWINC