-
WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD - Edge Gyms, Wira House Ring Road, West Park, Leeds, LS16 6EB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08293289
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Edge Gyms, Wira House Ring Road
- West Park
- Leeds
- LS16 6EB
- England Edge Gyms, Wira House Ring Road, West Park, Leeds, LS16 6EB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRISON, James
- HARRISON, Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-14 11 Jahre
- SIC/NACE
- 93130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Ben Riley
- Mr James Harrison
- -
- Mr Ben Riley
- Mr James Harrison
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WHITEROCK EXECUTIVE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-06-16
-
WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD Firmenbeschreibung
- WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08293289. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.11.2012 registriert. WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WHITEROCK EXECUTIVE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93130" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Edge Gyms, Wira House Ring Road erreicht werden.
Jetzt sichern WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Whiterock Executive (London) Ltd - Edge Gyms, Wira House Ring Road, West Park, Leeds, LS16 6EB, Grossbritannien
- 2012-11-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHITEROCK EXECUTIVE (LONDON) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-07-10) - SOAS(A)
-
gazette-notice-voluntary (2021-06-15) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-06-07) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-16) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-28) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-10-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-26) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-27) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-27) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-27) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-04) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-01) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-01) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2016-12-06) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-08-04) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-20) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-30) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-08-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-11-22) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-03) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-11-14) - NEWINC