-
REFRACTIV LIMITED - West One, 114 Wellington Street, Leeds, LS1 1BA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08260773
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- West One
- 114 Wellington Street
- Leeds
- LS1 1BA
- England West One, 114 Wellington Street, Leeds, LS1 1BA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ATKINSON, Richard Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-19 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian Mcneil
- Mr Ian Mcneill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- OUSECO 12 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-07-31
- Letzte Einreichung: 2021-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-02
- Letzte Einreichung: 2021-10-19
-
REFRACTIV LIMITED Firmenbeschreibung
- REFRACTIV LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08260773. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.10.2012 registriert. REFRACTIV LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OUSECO 12 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über West One erreicht werden.
Jetzt sichern REFRACTIV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Refractiv Limited - West One, 114 Wellington Street, Leeds, LS1 1BA, Grossbritannien
- 2012-10-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REFRACTIV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2019-03-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-11-02) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-02) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-27) - AA
-
memorandum-articles (2017-05-10) - MA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-01) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-14) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-11-14) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-14) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-03) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-11) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-12-11) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-12-12) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-18) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-11) - CERTNM
-
resolution (2012-10-31) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2012-10-31) - CONNOT
-
incorporation-company (2012-10-19) - NEWINC