-
BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. - 13, Morthen Road Morthen Road, Wickersley, Rotherham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08258137
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 13
- Morthen Road Morthen Road
- Wickersley
- Rotherham
- South Yorkshire
- S66 1ER
- England
- S66 1ER 13, Morthen Road Morthen Road, Wickersley, Rotherham, South Yorkshire, S66 1ER, England, S66 1ER UK
Management
- Geschäftsführung
- NEWHOUSE, Scott Paul Andrew
- O'DUILL, Darragh
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-18 11 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Scott Paul Andrew Newhouse
- -
- -
- Mr Darragh O'Duill
- -
- -
- -
- -
- Mr Darragh O'Duill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BLUE PLANET SOLAR HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-19
- Letzte Einreichung: 2020-11-05
-
BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. Firmenbeschreibung
- BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08258137. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.10.2012 registriert. BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BLUE PLANET SOLAR HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 13 erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue Planet Developments Ltd. - 13, Morthen Road Morthen Road, Wickersley, Rotherham, Grossbritannien
- 2012-10-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE PLANET DEVELOPMENTS LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-21) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-21) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-12) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-12) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-17) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-26) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-24) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-04) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-04) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-30) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-08) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-17) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-11-25) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-13) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-13) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-08-22) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-24) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-02) - AR01
-
change-of-name-notice (2014-12-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-10) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-27) - TM01
-
incorporation-company (2012-10-18) - NEWINC