-
AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED - The Business Park Maydwell Avenue, Slinfold, Horsham, RH13 0AS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08254763
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Business Park Maydwell Avenue
- Slinfold
- Horsham
- RH13 0AS
- England The Business Park Maydwell Avenue, Slinfold, Horsham, RH13 0AS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WHITESIDE, Christopher Angus Drake
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-16 11 Jahre
- SIC/NACE
- 52230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Avia Component Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- AVIA COMPONENT SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-26
- Letzte Einreichung: 2023-10-12
-
AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED Firmenbeschreibung
- AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08254763. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.10.2012 registriert. AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AVIA COMPONENT SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52230" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Business Park Maydwell Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ajw Technique Europe Limited - The Business Park Maydwell Avenue, Slinfold, Horsham, RH13 0AS, Grossbritannien
- 2012-10-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AJW TECHNIQUE EUROPE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-08-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-08) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-04-07) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-14) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2021-06-14) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-15) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-08) - AD01
-
resolution (2021-08-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-12) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-10) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-12) - AD01
-
resolution (2020-03-13) - RESOLUTIONS
-
resolution (2020-03-17) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-21) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-26) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-21) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-14) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-12-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-14) - AP01
-
incorporation-company (2012-10-16) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2012-11-20) - SH01