-
SQR SECURITY SOLUTIONS LTD - 165 Unit 2, Granville Road, London, NW2 2AZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08243074
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 165 Unit 2
- Granville Road
- London
- NW2 2AZ
- England 165 Unit 2, Granville Road, London, NW2 2AZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NAVAMA, Avi
- SLAGTER, Shai Isachar
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-08 11 Jahre
- SIC/NACE
- 80100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Shai Isachar Slagter
- Mr Avi Navama
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-07-30
- Letzte Einreichung: 2023-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-13
- Letzte Einreichung: 2023-06-29
-
SQR SECURITY SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- SQR SECURITY SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08243074. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.10.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "80100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2013 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 165 Unit 2 erreicht werden.
Jetzt sichern SQR SECURITY SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sqr Security Solutions Ltd - 165 Unit 2, Granville Road, London, NW2 2AZ, Grossbritannien
- 2012-10-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SQR SECURITY SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-06-29) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-06-29) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-29) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-01) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-01) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-07-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-07-20) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-11) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-11) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-04) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-12) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-22) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-26) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-11-04) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-11-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-20) - AD01
-
incorporation-company (2012-10-08) - NEWINC