-
WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED - 4 - 6 Dudley Road, Tunbridge Wells, TN1 1LF, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08213757
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 - 6 Dudley Road
- Tunbridge Wells
- TN1 1LF
- England 4 - 6 Dudley Road, Tunbridge Wells, TN1 1LF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DUNKLEY, Paul Kevin
- REED, Martin Victor
- WAUD, Jeremy Charles
- WINDASS, Christopher Martyn
- Prokuristen
- ATHEY, Martin Vivian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.09.2012
- Alter der Firma 2012-09-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 33120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WESTON ELECTRICAL SERVICES (WALES) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-23
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-27
- Letzte Einreichung: 2019-09-13
-
WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08213757. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.09.2012 registriert. WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WESTON ELECTRICAL SERVICES (WALES) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33120" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 4 - 6 Dudley Road erreicht werden.
Jetzt sichern WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Weston Electrical & Mechanical Services Limited - 4 - 6 Dudley Road, Tunbridge Wells, TN1 1LF, England, Grossbritannien
- 2012-09-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WESTON ELECTRICAL & MECHANICAL SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
legacy (2020-03-26) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-03-26) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-07) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-21) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-04-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-13) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-09-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-13) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-13) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-17) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-17) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-17) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-30) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-17) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-13) - PSC02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-01) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-01) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-28) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-22) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-09-21) - SH02
-
resolution (2016-09-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-06-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-16) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-20) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-19) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-11-11) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2013-11-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-09-13) - NEWINC