-
BNV LIMITED - Gladstone Place, 36-38 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08210135
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gladstone Place
- 36-38 Upper Marlborough Road
- St. Albans
- Hertfordshire
- AL1 3UU
- England Gladstone Place, 36-38 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, AL1 3UU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BANNISTER, William Bahlsen
- BIGGART, Thomas Mckenzie
- CLARKE, Jeremy
- LANE, Simon Paul
- Prokuristen
- PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.09.2012
- Gelöscht am:
- 2021-11-16
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Malthurst (Uk) Limited
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- BNV Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-25
- Letzte Einreichung: 2020-09-11
-
BNV LIMITED Firmenbeschreibung
- BNV LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08210135. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.09.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Gladstone Place erreicht werden.
Jetzt sichern BNV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bnv Limited - Gladstone Place, 36-38 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BNV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-08-24) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-08-31) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-16) - CS01
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-11-16) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-09-15) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-09-15) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-09-15) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-09-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-09-26) - AA
-
legacy (2019-09-26) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-09-26) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-09-26) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-11) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-16) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-18) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2019-03-31) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-03-31) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-11) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-09-25) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-19) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-06) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-07-04) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-06) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-05-06) - AA
-
auditors-resignation-company (2016-09-02) - AUD
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-16) - MR01
-
resolution (2016-12-29) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-12-29) - MA
-
auditors-resignation-company (2016-09-14) - AUD
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-sail-address-company (2013-09-13) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-13) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2013-09-13) - AD03
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-09) - MG01
-
incorporation-company (2012-09-11) - NEWINC