-
LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED - Castlegate House, 36 Castle Street, Hertford, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08204541
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Castlegate House
- 36 Castle Street
- Hertford
- Hertfordshire
- SG14 1HH Castlegate House, 36 Castle Street, Hertford, Hertfordshire, SG14 1HH UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.09.2012
- Gelöscht am:
- 2023-07-28
- SIC/NACE
- 82990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- INTEGRATED SIGNAGE SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-09-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-09-20
- Letzte Einreichung:
-
LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08204541. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.09.2012 registriert. LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen INTEGRATED SIGNAGE SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.09.2015.Die Firma kann schriftlich über Castlegate House erreicht werden.
Jetzt sichern LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Limitedspace Media Group Limited - Castlegate House, 36 Castle Street, Hertford, Hertfordshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIMITEDSPACE MEDIA GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting (2023-04-28) - WU15
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-07-28) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2022-07-05) - WU07
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-08-02) - WU07
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-removal-of-liquidator-by-court (2020-10-09) - WU14
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2020-09-21) - WU04
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-07-22) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-07-23) - WU07
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-07-23) - WU07
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2017-07-08) - WU07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-03) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-02) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-05) - AA
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2016-02-09) - COCOMP
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2016-05-28) - 4.31
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-06-01) - SH01
-
capital-allotment-shares (2015-06-04) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-08) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-06-08) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-06-19) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-26) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-18) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-06) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-05-29) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-12-04) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-10-17) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-28) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-08-28) - SH01
-
second-filing-of-form-with-form-type (2014-10-10) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-28) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-25) - MR01
-
resolution (2014-07-22) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-28) - TM01
-
capital-allotment-shares (2014-08-13) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-08-22) - SH01
-
resolution (2014-09-04) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-04) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-06-28) - AA01
-
change-of-name-notice (2013-08-14) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2013-08-14) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2013-08-29) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-09-05) - SH02
-
capital-allotment-shares (2013-08-30) - SH01
-
resolution (2013-09-05) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-12-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-09-06) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-05) - AP01