• UK
  • MCM FORECOURTS LTD - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
08195075
Firmenstatus
GELÖSCHT
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Office D Beresford House
Town Quay
Southampton
SO14 2AQ
Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK

Management

Geschäftsführung
BARRETT, Joseph James
DIVINEY, John
Prokuristen
-

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
29.08.2012
Gelöscht am:
2022-03-23
SIC/NACE
47300

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
-
-
-
Petrogas Group Uk Limited
-

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
dissolved
Ehemalige Namen
WISBECH ROAD SERVICE STATION LIMITED
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2020-05-31
Letzte Einreichung: 2018-08-31
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2020-09-27
Letzte Einreichung: 2019-08-16

MCM FORECOURTS LTD Firmenbeschreibung

MCM FORECOURTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08195075. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.08.2012 registriert. MCM FORECOURTS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WISBECH ROAD SERVICE STATION LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47300" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Office D Beresford House erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern MCM FORECOURTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Mcm Forecourts Ltd - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MCM FORECOURTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-03-15) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-director-appointment-with-name (2021-09-09) - RP04AP01

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-secretary-termination-with-name (2021-09-09) - RP04TM02

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-09) - RP04PSC02

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-09-09) - RP04CS01

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-director-termination-with-name (2021-09-10) - RP04TM01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-02-04) - LIQ01

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2020-01-31) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-01-31) - LIQ01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-31) - 600

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-03) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-02) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-full (2019-05-30) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2018-10-09) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-06) - AA

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-03) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-09-05) - RP04AR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-27) - AA

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC01

    In den Warenkorb
     
  • change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC04

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-16) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-15) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-11-15) - TM02

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-15) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-21) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-22) - PSC02

    In den Warenkorb
     
  • second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-08-15) - RP04AR01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2017-08-15) - RP04CS01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-01) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-23) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-10) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-04) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-03) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-20) - AA

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-07) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • certificate-change-of-name-company (2014-10-07) - CERTNM

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-30) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-27) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-19) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-04) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2012-09-17) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2012-08-29) - NEWINC

    In den Warenkorb
     
  • memorandum-articles (2012-09-06) - MEM/ARTS

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2012-09-14) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-17) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-25) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2012-09-19) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2012-09-21) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2012-10-25) - MG01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-secretary-company-with-name (2012-09-14) - AP03

    In den Warenkorb
     
  • certificate-change-of-name-company (2012-09-14) - CERTNM

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name (2012-09-14) - TM02

    In den Warenkorb
     
expand_less