-
SIGNAL PLASTIC COMPONENTS LIMITED - Omega Group Kingsway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, NE11 0JL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08177790
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Omega Group Kingsway South
- Team Valley Trading Estate
- Gateshead
- NE11 0JL
- England Omega Group Kingsway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, NE11 0JL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CRONE, David
- JAMIESON, Julian
- OWEN, Gary
- SAYER, Peter Allen
- SWINHOE, Craig Robert
- THOMPSON, Christopher Scott
- Prokuristen
- WILSON, Lynn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Omega Plastics Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-27
- Letzte Einreichung: 2020-08-13
-
SIGNAL PLASTIC COMPONENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- SIGNAL PLASTIC COMPONENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08177790. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.08.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Omega Group Kingsway South erreicht werden.
Jetzt sichern SIGNAL PLASTIC COMPONENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Signal Plastic Components Limited - Omega Group Kingsway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, NE11 0JL, Grossbritannien
- 2012-08-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIGNAL PLASTIC COMPONENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-10) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-18) - AP01
-
accounts-amended-with-accounts-type-small (2020-11-04) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-05) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-05) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-07-05) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-30) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-01-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-03-02) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-02) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-17) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-13) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-19) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-12) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-02-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-05) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-08-13) - NEWINC