-
WICKED COATINGS LIMITED - 44, Holton Road, Holton Heath Trading Park, Poole, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08170661
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 44
- Holton Road
- Holton Heath Trading Park
- Poole
- Dorset
- BH16 6LT 44, Holton Road, Holton Heath Trading Park, Poole, Dorset, BH16 6LT UK
Management
- Geschäftsführung
- HINKS, Christopher James
- MEIKLE, Lyle Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Christopher James Hinks
- Mr Lyle Robert Meikle
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-18
- Letzte Einreichung: 2019-08-07
-
WICKED COATINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- WICKED COATINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08170661. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.08.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 44 erreicht werden.
Jetzt sichern WICKED COATINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wicked Coatings Limited - 44, Holton Road, Holton Heath Trading Park, Poole, Grossbritannien
- 2012-08-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WICKED COATINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-09) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-09) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-08) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-06) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-16) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-17) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-24) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-10) - AR01
-
resolution (2014-09-11) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-09-11) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-08) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-09-17) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-29) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-07) - AP01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-09-11) - SH10
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-10-04) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-04) - AP01
-
incorporation-company (2012-08-07) - NEWINC