-
CONNACHT SPV 2 LIMITED - C/O HILL DICKINSON LLP, No 1 St Pauls Square, Liverpool, L3 9SJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08170160
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O HILL DICKINSON LLP
- No 1 St Pauls Square
- Liverpool
- L3 9SJ C/O HILL DICKINSON LLP, No 1 St Pauls Square, Liverpool, L3 9SJ UK
Management
- Geschäftsführung
- FAHERTY, Patrick Gerald Francis
- WALDRON, Patrick Gerard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.08.2012
- Gelöscht am:
- 2021-01-14
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Connacht Spv 1 Ltd
- Eurazeo S.A.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- EXPONENT (CONNACHT) SPV 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-21
- Letzte Einreichung: 2018-08-07
-
CONNACHT SPV 2 LIMITED Firmenbeschreibung
- CONNACHT SPV 2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08170160. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.08.2012 registriert. CONNACHT SPV 2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EXPONENT (CONNACHT) SPV 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Hill Dickinson Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CONNACHT SPV 2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Connacht Spv 2 Limited - C/O HILL DICKINSON LLP, No 1 St Pauls Square, Liverpool, L3 9SJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONNACHT SPV 2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-04-19) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-04-19) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-17) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-04-19) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-11-01) - SH08
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-24) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-16) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-09-10) - AA01
-
resolution (2018-11-01) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-11-01) - CAP-SS
-
legacy (2018-01-04) - RP04CS01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-11-01) - SH19
-
legacy (2018-11-01) - SH20
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-11-01) - SH10
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-11-01) - SH02
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-29) - MR01
-
resolution (2017-12-18) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-18) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-17) - TM02
-
auditors-resignation-limited-company (2016-07-19) - AA03
-
resolution (2016-03-10) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-02-17) - RP04
-
capital-allotment-shares (2016-01-29) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-27) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
memorandum-articles (2015-10-20) - MA
-
resolution (2015-10-20) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-15) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-12) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-16) - AP03
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-10-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-10-09) - SH01
-
resolution (2013-10-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-09-10) - SH01
-
change-of-name-notice (2012-08-14) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-08-14) - CERTNM
-
resolution (2012-09-07) - RESOLUTIONS
-
capital-redomination-of-shares (2012-09-07) - SH14
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-10) - AD01
-
capital-alter-shares-subdivision (2012-09-10) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-10) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-09-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-09-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-09-10) - AA01
-
incorporation-company (2012-08-07) - NEWINC