-
ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED - Suite 2,, Pure Offices Port Way, Port Solent, Portsmouth, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08163038
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 2,
- Pure Offices Port Way
- Port Solent
- Portsmouth
- Hampshire
- PO6 4TY
- United Kingdom Suite 2,, Pure Offices Port Way, Port Solent, Portsmouth, Hampshire, PO6 4TY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLT, David Andrew
- O'MALLEY, Margarita
- READ, Christopher Dunstan Boileau
- CALMONSON, David Henry
- CHAPLIN, Andrew
- HENDRY, Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-31 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr David Andrew Holt
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DUNSTAN THOMAS ENERGY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-07
- Letzte Einreichung: 2021-02-21
-
ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08163038. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.07.2012 registriert. ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DUNSTAN THOMAS ENERGY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite 2 erreicht werden.
Jetzt sichern ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Enegen Power Systems Limited - Suite 2,, Pure Offices Port Way, Port Solent, Portsmouth, Grossbritannien
- 2012-07-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENEGEN POWER SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-21) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-02-21) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-21) - PSC01
-
capital-allotment-shares (2021-02-20) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-03) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-26) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-12) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-07-13) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-17) - CH01
-
resolution (2020-05-27) - RESOLUTIONS
-
legacy (2020-06-23) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-06-23) - GUARANTEE2
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-09-09) - AA
-
legacy (2020-09-09) - PARENT_ACC
-
resolution (2020-09-08) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-14) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-06) - AP01
-
memorandum-articles (2020-09-08) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-15) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-27) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-23) - TM01
-
resolution (2016-03-11) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-06) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-17) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-04-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-10-02) - AA01
-
incorporation-company (2012-07-31) - NEWINC