-
DUNSTAN THOMAS CONSULTING LIMITED - Building 3000 Lakeside North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08162530
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Building 3000 Lakeside North Harbour
- Portsmouth
- Hampshire
- PO6 3EN
- United Kingdom Building 3000 Lakeside North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ALDRIDGE, Luisa Jane
- EL-SAIE, Ihab Mahmoud Hassan Ali
- FINTZ, Julia
- MARTIN, Andrew John
- O'MALLEY, Margarita
- READ, Christopher Dunstan Boileau
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-31 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dunstan Thomas Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-15
- Letzte Einreichung: 2020-10-01
-
DUNSTAN THOMAS CONSULTING LIMITED Firmenbeschreibung
- DUNSTAN THOMAS CONSULTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08162530. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Building 3000 Lakeside North Harbour erreicht werden.
Jetzt sichern DUNSTAN THOMAS CONSULTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dunstan Thomas Consulting Limited - Building 3000 Lakeside North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, Grossbritannien
- 2012-07-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUNSTAN THOMAS CONSULTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-09) - MR01
-
legacy (2020-06-23) - AGREEMENT2
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-06) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-17) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-10) - AP01
-
legacy (2020-06-23) - GUARANTEE2
-
memorandum-articles (2020-09-11) - MA
-
resolution (2020-09-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-09) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-09-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-07) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-01) - TM01
-
legacy (2020-09-09) - PARENT_ACC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-09-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-14) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-15) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-15) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-17) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-27) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-27) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-05) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-02) - AP01
-
resolution (2016-03-11) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-18) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-04-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-10-02) - AA01
-
incorporation-company (2012-07-31) - NEWINC