-
HOLLINBERRY ESTATES LIMITED - Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08156463
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D
- Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 68310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Michael Patterson
- Mr Michael Patterson
- Bloom Property Services Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- HARPER BROOKS (UK) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-12-31
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-06
- Letzte Einreichung: 2017-06-22
-
HOLLINBERRY ESTATES LIMITED Firmenbeschreibung
- HOLLINBERRY ESTATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08156463. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.07.2012 registriert. HOLLINBERRY ESTATES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HARPER BROOKS (UK) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68310" registriert. Die Firma kann schriftlich über Office D erreicht werden.
Jetzt sichern HOLLINBERRY ESTATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hollinberry Estates Limited - Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, Grossbritannien
- 2012-07-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOLLINBERRY ESTATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-04-13) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-09-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-18) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-04) - TM01
-
liquidation-change-of-membership-of-creditors-or-liquidation-committee (2018-11-06) - COM2
-
liquidation-establishment-of-creditors-or-liquidation-committee (2018-10-30) - COM1
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-21) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-20) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-07) - AD01
-
resolution (2018-09-06) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-04) - AP01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-03-10) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-06) - TM01
-
resolution (2017-04-28) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-05) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-31) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-03-31) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-04) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-17) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-12-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-06) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-22) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2013-05-22) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-22) - AP03
-
incorporation-company (2012-07-25) - NEWINC