-
CAPEN LIMITED - C/O Kre Coporate Recovery Limited Unit 8 The Aquarium, 1-7 King Street, Reading, RG1 2AN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08141955
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Kre Coporate Recovery Limited Unit 8 The Aquarium
- 1-7 King Street
- Reading
- RG1 2AN C/O Kre Coporate Recovery Limited Unit 8 The Aquarium, 1-7 King Street, Reading, RG1 2AN UK
Management
- Geschäftsführung
- MCBRIAR, Richard Alexander
- RYDINGS, Simon James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Isfield Nominees Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- CAPEN CONSULTANTS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-26
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-16
- Letzte Einreichung: 2020-05-02
-
CAPEN LIMITED Firmenbeschreibung
- CAPEN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08141955. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.07.2012 registriert. CAPEN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CAPEN CONSULTANTS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Kre Coporate Recovery Limited Unit 8 The Aquarium erreicht werden.
Jetzt sichern CAPEN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Capen Limited - C/O Kre Coporate Recovery Limited Unit 8 The Aquarium, 1-7 King Street, Reading, RG1 2AN, Grossbritannien
- 2012-07-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAPEN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-04-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-03-10) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-10) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-03-19) - 600
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-24) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-29) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-06-30) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-01-11) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-07-24) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-26) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-24) - GAZ1
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-04-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-08) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-04-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-10-18) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-01) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-01) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-01) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-01) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-05-15) - SH01
-
resolution (2017-05-12) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-04-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-07-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-10) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-07-06) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-01-06) - SH01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-02-05) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-06) - AP01
-
resolution (2016-01-06) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-01-06) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-03-16) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-03-17) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-05-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-13) - NEWINC