-
UTTLEY MEMORIALS LIMITED - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08128354
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2-3 Winckley Court Chapel Street
- Preston
- PR1 8BU 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU UK
Management
- Geschäftsführung
- PARRY, David William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-03 11 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Uttley
- Mr Sean Uttley
- Mr Sean Uttley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-05-31
- Letzte Einreichung: 2018-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-05
- Letzte Einreichung: 2019-05-22
-
UTTLEY MEMORIALS LIMITED Firmenbeschreibung
- UTTLEY MEMORIALS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08128354. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 2-3 Winckley Court Chapel Street erreicht werden.
Jetzt sichern UTTLEY MEMORIALS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Uttley Memorials Limited - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
- 2012-07-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UTTLEY MEMORIALS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-05-23) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-01-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-14) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-08-14) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-11-26) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-11-26) - 600
-
resolution (2019-11-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-23) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-24) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-13) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-07) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-02-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-03) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-21) - AP01