-
OPTICAL DISPENSING LTD - Wey Court West, Union Road, Farnham, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08113860
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wey Court West
- Union Road
- Farnham
- Surrey
- GU9 7PT Wey Court West, Union Road, Farnham, Surrey, GU9 7PT UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWCROFT, Jonathon Toby
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-21 11 Jahre
- SIC/NACE
- 47782
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Caroline Joan Elderton
- -
- Mr Jonathon Toby Howcroft
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ODIHAM OPTICAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-26
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-05
- Letzte Einreichung: 2023-06-21
-
OPTICAL DISPENSING LTD Firmenbeschreibung
- OPTICAL DISPENSING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08113860. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.06.2012 registriert. OPTICAL DISPENSING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ODIHAM OPTICAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47782" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Wey Court West erreicht werden.
Jetzt sichern OPTICAL DISPENSING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Optical Dispensing Ltd - Wey Court West, Union Road, Farnham, Surrey, Grossbritannien
- 2012-06-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OPTICAL DISPENSING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-21) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-06-24) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-24) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-08-23) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-09-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-19) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-22) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-01-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-23) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-25) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-07-27) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-06-24) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-26) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-29) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-06-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-of-name-notice (2014-12-16) - CONNOT
-
resolution (2014-11-28) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-21) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-16) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-12-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-18) - AP01
-
incorporation-company (2012-06-21) - NEWINC